Our Family Genealogy Pages
Discovering our Ancestors
First Name
Last Name
[Advanced Search]
[Surnames]
Find
Surnames
First Names
Search People
Search Families
Search Site
Places
Dates
Calendar
Cemeteries
Bookmarks
Media
Photos
Documents
Headstones
Histories
Recordings
Videos
All Media
Info
What's New
Most Wanted
Reports
Statistics
Trees
Branches
Notes
Sources
Repositories
DNA Tests
Contact Us
Home
Search
Login
Search
|
Advanced Search
|
Search Families
|
Search Site
First Name:
Last Name:
ID:
Print
Bookmark
George Cornish
1540 - 1607 (67 years)
Individual
Ancestors
Descendants
Relationship
Timeline
Family
GEDCOM
Suggest
Generations:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Standard
|
Compact
|
Vertical
|
Text
|
Register
|
Tables
|
PDF
(
= Descendancy chart to this point,
= Expand,
= Collapse)
Expand all
|
Collapse all
1
George Cornish
[1]
b. 1540 d. 6 Feb 1607
Maria Mary Lawrence Cornish
b. 1560 d. 15 Sep 1622
2
Richard Cornish
[1.1]
b. 25 Jan 1578 d. 29 Sept 1625
Grace Goodinge
b. 27 June 1587 d. 26 July 1658
3
Jane Cornish
[1.1.1]
b. 1603 d. Sep 1674
3
Thomas Cornish
[1.1.2]
b. 1610 d. 14 Feb 1662
3
John Cornish
[1.1.3]
b. 14 Mar 1610 d. 1610
3
Jane Cornish
[1.1.4]
b. 15 Aug 1612 d. Sep 1674
Edward Robins
b. 3 Nov 1602 d. 17 May 1641
4
Rachel Jane Robins
[1.1.4.1]
b. November 1631 d. 10 Aug 1681
Richard Beard, III
b. 1 Jan 1626 d. 29 Aug 1681
5
Rachel Beard
[1.1.4.1.1]
b. 1650 d. 11 Jun 1724
Capt John Gaither, III
b. 26 Jan 1635 d. 12 Nov 1702
6
John Benjamin Gaither, IV
[1.1.4.1.1.1]
b. 15 Jan 1677 d. 4 May 1739
+
Sarah (Sary) Burgess
b. 1690 d. 14 Nov 1769
Elizabeth Duvall
b. 4 Aug 1687 d. 22 Nov 1770
7
John Gaither
[1.1.4.1.1.1.1]
b. 24 Apr 1713 d. 6 Sep 1784
7
Edward Gaither
[1.1.4.1.1.1.2]
b. 20 Dec 1714 d. 11 Jun 1777
7
Alexander Gaither
[1.1.4.1.1.1.3]
b. Abt 1720
7
Ruth Gaither
[1.1.4.1.1.1.4]
b. 15 Nov 1721 d. 1790
Robert Davis
b. 1723 d. 1789
8
Nicholas Davis
[1.1.4.1.1.1.4.1]
b. Abt 1745
8
Ely Davis
[1.1.4.1.1.1.4.2]
b. 1747 d. 1794
8
Robert Davis
[1.1.4.1.1.1.4.3]
b. 1749 d. 1830
8
Thomas Davis, Sr.
[1.1.4.1.1.1.4.4]
b. Abt 1755
8
Ichabod Davis
[1.1.4.1.1.1.4.5]
b. 1758 d. 1845
7
Rezin Gaither
[1.1.4.1.1.1.5]
b. 1726 d. 1807
Sarah Yieldhall
b. 29 Mar 1726 d. 1762
8
Rezin Gaither
[1.1.4.1.1.1.5.1]
b. 1750 d. 1798
8
Ruth Gaither
[1.1.4.1.1.1.5.2]
b. 1750
8
Elizabeth Gaither
[1.1.4.1.1.1.5.3]
b. 1750
8
Henry Gaither
[1.1.4.1.1.1.5.4]
b. 1751 d. 22 Jun 1811
8
Rebecca Elizabeth Gaither
[1.1.4.1.1.1.5.5]
b. 1762 d. 1823
William Robert Eades
b. 07 Aug 1762 d. 05 Jul 1822
9
George C Eades
[1.1.4.1.1.1.5.5.1]
b. Abt 1780 d. Abt 1849
Juliet Amanda Campbell
b. 1782 d. Bef 1849
10
Permelia Eades
[1.1.4.1.1.1.5.5.1.1]
b. 04 Jan 1802 d. 22 Mar 1838
10
Matilda Eades
[1.1.4.1.1.1.5.5.1.2]
b. 1806
10
Marcalet Elizabeth Eades
[1.1.4.1.1.1.5.5.1.3]
b. Jan 1811 d. 10 May 1875
Moses Whitley
b. May 1810 d. Jun 1891
11
William Whitley
[1.1.4.1.1.1.5.5.1.3.1]
b. 1832
11
Nancy Elizabeth Whitley
[1.1.4.1.1.1.5.5.1.3.2]
b. 13 September 1834 d. 28 February 1913
Nathaniel Warren
b. Abt 1835 d. Bef 1865
12
Susan Mary Warren
[1.1.4.1.1.1.5.5.1.3.2.1]
b. 9 Nov 1858 d. 23 May 1934
12
Samuel W Warren
[1.1.4.1.1.1.5.5.1.3.2.2]
b. 7 Jan 1861 d. 26 Feb 1946
11
Amanda Camel Whitney
[1.1.4.1.1.1.5.5.1.3.3]
b. 7 Mar 1836 d. 31 Dec 1925
William MCDANIEL
d. Bet. 1852–1858
12
Nancy E MCDANIEL
[1.1.4.1.1.1.5.5.1.3.3.1]
b. 1856
12
John W MCDANIEL
[1.1.4.1.1.1.5.5.1.3.3.2]
b. Dec 1859
William Henry ROUSE
b. 07 Dec 1828 d. 29 Aug 1902
12
Mary Arena ROUSE
[1.1.4.1.1.1.5.5.1.3.3.3]
b. 26 Jun 1859 d. 11 Feb 1922
12
Rebecca J ROUSE
[1.1.4.1.1.1.5.5.1.3.3.4]
b. Abt. 1860
12
Alice R Rouse
[1.1.4.1.1.1.5.5.1.3.3.5]
b. 1 Dec 1869 d. 22 Aug 1930
12
Solomon Rouse
[1.1.4.1.1.1.5.5.1.3.3.6]
b. 08 Dec 1871 d. 16 Dec 1922 [
=>
]
12
Ada ROUSE
[1.1.4.1.1.1.5.5.1.3.3.7]
b. 02 Feb 1874 d. 28 Jan 1901
12
Ida ROUSE
[1.1.4.1.1.1.5.5.1.3.3.8]
b. 16 Oct 1876 d. 16 Aug 1964
12
Moses ROUSE
[1.1.4.1.1.1.5.5.1.3.3.9]
b. 14 May 1880 d. 29 Sep 1880
11
Mary L Whitley
[1.1.4.1.1.1.5.5.1.3.4]
b. 1838
11
James W Whitley
[1.1.4.1.1.1.5.5.1.3.5]
b. 1848 d. 18 Sep 1875
11
Alfred A Whitley
[1.1.4.1.1.1.5.5.1.3.6]
b. 1850
11
John H Whitley
[1.1.4.1.1.1.5.5.1.3.7]
b. Abt 1852
11
Eliza Jane Whitley
[1.1.4.1.1.1.5.5.1.3.8]
b. Abt 1853
10
Nancy Hamilton Eades
[1.1.4.1.1.1.5.5.1.4]
b. 30 Jul 1813 d. 07 Sep 1855
Elijah Phillips
b. 29 Jul 1801 d. 29 Mar 1877
11
Sarah Elizabeth Phillips
[1.1.4.1.1.1.5.5.1.4.1]
b. 11 Oct 1832 d. 6 Mar 1923
William Andrew Bowen
b. 5 May 1830 d. 5 May 1907
12
John W. Bowen
[1.1.4.1.1.1.5.5.1.4.1.1]
b. Abt 1853 d. 29 October 1936
12
William Andrew Bowen
[1.1.4.1.1.1.5.5.1.4.1.2]
b. 7 May 1854 d. 2 January 1902 [
=>
]
12
Elijah Redford Bowen
[1.1.4.1.1.1.5.5.1.4.1.3]
b. 29 Jun 1856 d. 6 April 1938
12
David O Bowen
[1.1.4.1.1.1.5.5.1.4.1.4]
b. 8 December 1860 d. 16 March 1912
12
Mattie Bowen
[1.1.4.1.1.1.5.5.1.4.1.5]
b. Mar 1870
12
Sarah Martha Johns
[1.1.4.1.1.1.5.5.1.4.1.6]
b. 7 November 1870 d. 29 February 1908
11
William Elonza Phillips
[1.1.4.1.1.1.5.5.1.4.2]
b. 7 Sep 1834 d. 26 Nov 1913
11
Mary Letitia Phillips
[1.1.4.1.1.1.5.5.1.4.3]
b. Abt 1837 d. Bef 1900
11
Samuel Anderson Phillips
[1.1.4.1.1.1.5.5.1.4.4]
b. 28 Feb 1838 d. 19 May 1930
11
John Phillips
[1.1.4.1.1.1.5.5.1.4.5]
b. 29 Sep 1841 d. 11 Dec 1929
11
Mary Louisa Phillips
[1.1.4.1.1.1.5.5.1.4.6]
b. 12 Apr 1844 d. 27 Dec 1886
11
Samintha A Phillips
[1.1.4.1.1.1.5.5.1.4.7]
b. 26 Aug 1847 d. 2 Jun 1924
11
Mary Etta Phillips
[1.1.4.1.1.1.5.5.1.4.8]
b. 13 Feb 1850 d. 5 Mar 1888
11
Elijah Phillips
[1.1.4.1.1.1.5.5.1.4.9]
b. Jan 1852 d. Aft 1880
10
Alonzo Catlett Eades
[1.1.4.1.1.1.5.5.1.5]
b. Abt 1818
10
Rutha P. Eades
[1.1.4.1.1.1.5.5.1.6]
b. 08 Oct 1819 d. 16 Sep 1902
Nathaniel Phillips
b. 6 May 1816 d. 7 Jul 1876
11
Permelia Victoria Phillips
[1.1.4.1.1.1.5.5.1.6.1]
b. 24 Jul 1838 d. 26 Dec 1908
11
Ann Eliza Phillips
[1.1.4.1.1.1.5.5.1.6.2]
b. 3 Apr 1843 d. 12 Dec 1914
Joseph Marion Daugherty
b. 22 May 1841 d. 18 May 1921
12
Unnamed Daugherty
[1.1.4.1.1.1.5.5.1.6.2.1]
b. 27 Aug 1876 d. 27 Aug 1876
12
Ruth Virginia Daugherty
[1.1.4.1.1.1.5.5.1.6.2.2]
b. 16 Aug 1880 d. 25 Nov 1939
11
Henrietta Phillips
[1.1.4.1.1.1.5.5.1.6.3]
b. 30 Oct 1845 d. 29 Jan 1921
11
James Madison Phillips, Reverend
[1.1.4.1.1.1.5.5.1.6.4]
b. Abt 1848 d. Mar 1886
11
Blanford S Phillips
[1.1.4.1.1.1.5.5.1.6.5]
b. 23 Nov 1852 d. 3 Jul 1905
11
Nancy Ellen Phillips
[1.1.4.1.1.1.5.5.1.6.6]
b. 6 Sep 1853 d. 19 Apr 1943
11
David Morton Phillips
[1.1.4.1.1.1.5.5.1.6.7]
b. Oct 1855 d. Oct 1931
11
Nathan Donaldson Phillips
[1.1.4.1.1.1.5.5.1.6.8]
b. 16 Jul 1861 d. 7 Oct 1938
Louteshie Belle Hoskins
b. 2 Dec 1860 d. 26 Jul 1947
12
James Ervin Phillips
[1.1.4.1.1.1.5.5.1.6.8.1]
b. 4 Oct 1879 d. 20 Mar 1967 [
=>
]
12
Sarah Elizabeth Phillips
[1.1.4.1.1.1.5.5.1.6.8.2]
b. 31 Dec 1880 d. 30 Dec 1967
12
Ella Parish Phillips
[1.1.4.1.1.1.5.5.1.6.8.3]
b. 19 Jan 1885 d. 25 Nov 1970
12
Mary Etta Phillips
[1.1.4.1.1.1.5.5.1.6.8.4]
b. 16 Jul 1887 d. 20 Jan 1927
12
Lawrence William Phillips
[1.1.4.1.1.1.5.5.1.6.8.5]
b. 21 Sep 1889 d. 9 Feb 1976
12
Clara Bell Phillips
[1.1.4.1.1.1.5.5.1.6.8.6]
b. 27 Jan 1892 d. 5 Feb 1927
12
Lee Ona "Lona" Phillips
[1.1.4.1.1.1.5.5.1.6.8.7]
b. 1 Aug 1894 d. 18 Aug 1994
12
Nora Jennie Phillips
[1.1.4.1.1.1.5.5.1.6.8.8]
b. 22 Feb 1897 d. 25 Feb 1970
12
Leslie Morris Phillips
[1.1.4.1.1.1.5.5.1.6.8.9]
b. 29 Dec 1901 d. 24 Sep 1968
10
Rebecca A Eades
[1.1.4.1.1.1.5.5.1.7]
b. 23 Jan 1826 d. 2 Oct 1896
Gabriel Warren
b. October 1824 d. July 1909
11
Therrissa Warren
[1.1.4.1.1.1.5.5.1.7.1]
b. 1848 d. 9 Oct 1872
Warren Elmore
b. 14 Mar 1840 d. 24 Jan 1885
12
Laura C. Elmore
[1.1.4.1.1.1.5.5.1.7.1.1]
b. 30 Aug 1872 d. 16 Feb 1962 [
=>
]
11
Martha J. Warren
[1.1.4.1.1.1.5.5.1.7.2]
b. 6 Mar 1850 d. 7 Feb 1918
Lutanis "Luther" Towne Towns
b. 20 Aug 1845 d. 28 Sep 1920
12
Robert B Towne
[1.1.4.1.1.1.5.5.1.7.2.1]
b. 15 Aug 1869 d. 9 Mar 1942 [
=>
]
12
Rebecca Jane Towne
[1.1.4.1.1.1.5.5.1.7.2.2]
b. 04 Jan 1874 d. 9 Aug 1929 [
=>
]
12
Rufus C Towne
[1.1.4.1.1.1.5.5.1.7.2.3]
b. Apr 1876
12
Luella Lee Towne
[1.1.4.1.1.1.5.5.1.7.2.4]
b. 19 May 1877 d. 14 Nov 1939
12
Walter Ralph Towns
[1.1.4.1.1.1.5.5.1.7.2.5]
b. 19 Nov 1881 d. 8 Feb 1970 [
=>
]
12
Oscar Avo Town
[1.1.4.1.1.1.5.5.1.7.2.6]
b. 24 Feb 1883 d. 19 Jun 1964 [
=>
]
12
William Towne
[1.1.4.1.1.1.5.5.1.7.2.7]
b. May 1885 d. 1 Nov 1918
11
Susan M Warren
[1.1.4.1.1.1.5.5.1.7.3]
b. 12 Jun 1852
11
William L Warren
[1.1.4.1.1.1.5.5.1.7.4]
b. 11 Aug 1856 d. 16 Sep 1867
11
George Washington Warren
[1.1.4.1.1.1.5.5.1.7.5]
b. 4 Dec 1858 d. 24 Aug 1872
11
James Gabriel Warren
[1.1.4.1.1.1.5.5.1.7.6]
b. 23 Mar 1860 d. 18 Jul 1893
12
George Franklin Warren
[1.1.4.1.1.1.5.5.1.7.6.1]
b. November 1885 d. 6 December 1957 [
=>
]
11
Elijah Warren
[1.1.4.1.1.1.5.5.1.7.7]
b. 29 Aug 1864 d. 11 Nov 1905
Harriett F Wise
b. 19 Jan 1863 d. 10 Jun 1940
12
Rosettie Warren
[1.1.4.1.1.1.5.5.1.7.7.1]
b. Feb 1884 [
=>
]
12
Everett Warren
[1.1.4.1.1.1.5.5.1.7.7.2]
b. Sep 1887 [
=>
]
11
Alonzo Edward Warren, MD
[1.1.4.1.1.1.5.5.1.7.8]
b. 11 Oct 1866 d. 13 Aug 1897
11
Thomas Warren
[1.1.4.1.1.1.5.5.1.7.9]
b. 1 March 1869 d. 8 Jul 1958
Burley Dean Davis
b. 4 Jul 1872 d. 25 Feb 1951
12
John Arthur Warren
[1.1.4.1.1.1.5.5.1.7.9.1]
b. 15 May 1914 d. 20 Dec 1988
12
Myrtle Francis Warren
[1.1.4.1.1.1.5.5.1.7.9.2]
b. Dec 1891 d. Jan 1970 [
=>
]
10
Juliet Frances Eades
[1.1.4.1.1.1.5.5.1.8]
b. 18 Jul 1833 d. 10 Mar 1879
10
Louisa Eades
[1.1.4.1.1.1.5.5.1.9]
10
Malissa Eades
[1.1.4.1.1.1.5.5.1.10]
9
Robert C. EADES
[1.1.4.1.1.1.5.5.2]
b. 1785 d. 01 Jun 1876
10
Charles William EADES
[1.1.4.1.1.1.5.5.2.1]
b. 18 Sep 1818 d. 11 May 1876
11
Adah Emaline Eads
[1.1.4.1.1.1.5.5.2.1.1]
b. 13 May 1851 d. 1923-02-25
10
Mary Elds
[1.1.4.1.1.1.5.5.2.2]
11
Melinda Ellen Speaks
[1.1.4.1.1.1.5.5.2.2.1]
b. 17 Dec 1842 d. 25 Apr 1909
9
Thomas Eades
[1.1.4.1.1.1.5.5.3]
b. Abt 1785 d. Aft 1840
10
Elijah Eads
[1.1.4.1.1.1.5.5.3.1]
b. 1808 d. Aug 1877
9
Elizabeth Eades
[1.1.4.1.1.1.5.5.4]
b. Abt 1791 d. 15 May 1875
8
Joshua Fillmore Gaither
[1.1.4.1.1.1.5.6]
d. 1844
Agnes Rogers
7
Mary Gaither
[1.1.4.1.1.1.6]
b. 04 Oct 1724 d. October 24, 1772
Seth Warfield
b. 15 January 1723 d. 1805
8
Benjamin Warfield
[1.1.4.1.1.1.6.1]
b. 1755 d. October 1829
Ariana Dorsey
9
Daniel Warfield
[1.1.4.1.1.1.6.1.1]
Nancy Anne Mactier
b. 25 Feb 1796 d. 16 March 1868
10
Henry Mactier Warfield
[1.1.4.1.1.1.6.1.1.1]
b. 24 Nov 1826 d. 17 Jan 1885
Anna Emory
b. 14 December 1830 d. 17 December 1915
11
Teackle Wallis Warfield
[1.1.4.1.1.1.6.1.1.1.1]
b. 8 Feb 1869 d. 15 Nov 1896
Alice Montague
b. 30 November 1869 d. 2 November 1929
12
Bessie Wallis Warfield
[1.1.4.1.1.1.6.1.1.1.1.1]
b. 19 Jun 1896 d. 24 Apr 1986
6
Mary Gaither
[1.1.4.1.1.2]
b. 13 Apr 1692 d. 1735
+
Joseph White
Thomas Stimpson
b. 1662 d. 1688
6
Comfort Rebekath Stimpson
[1.1.4.1.1.3]
b. 1686 d. 23 Jun 1747
+
John Dorsey, Jr
b. 1682 d. 12 Feb 1774
Col John Northington Dorsey, Jr
b. 15 June 1688 d. 13 Nov 1735
7
Sarah Rachel Dorsey
[1.1.4.1.1.3.1]
b. 15 October 1715 d. 25 Sep 1789
+
Robert Shipley
b. 1713
8
Lucy Shipley
[1.1.4.1.1.3.1.1]
b. 1765 d. 1825
9
Nancy Hanks
[1.1.4.1.1.3.1.1.1]
b. 1784 d. 1818
Thomas Lincoln
10
Abraham Lincoln
[1.1.4.1.1.3.1.1.1.1]
b. 12 Feb 1809 d. 15 Apr 1865
3
Elizabeth Robins
[1.1.5]
b. 15 Aug 1612 d. Aft. Aug 1674
3
Alice Cornish
[1.1.6]
b. 28 Aug 1614 d. 1674
3
Thomas Cornish
[1.1.7]
b. 1616 d. 18 Apr 1654
3
Grace Cornish
[1.1.8]
b. 14 Feb 1619 d. 1714
3
James Cornish
[1.1.9]
d. Nov 1635
+
Catherine Richard
b. 1584 d. 1644
+
Rebecca Cornish
b. 1578 d. 1678